
Elizabeth Norton

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Elizabeth Norton [1] b. Abt 1508 d. 23 Jun 1596
John William Ponder b. 1523 d. 20 Dec 1620
- 2 John Ponder [1.1]
b. Abt 1548 d. 20 Dec 1620
Alice Ethelreda Coke b. 1547 d. 28 Mar 1602
- 3 William Pond [1.1.1]
b. 1567 d. Oct 1637
Judith Gordon b. 1575 d. 1620
- 4 Robert Pond [1.1.1.1]
b. 10 Sep 1592 d. 20 Dec 1637
Mary Margaret Ball b. 1596 d. 20 Aug 1680
- 5 Robert Pond, Jr [1.1.1.1.1]
b. Abt 1626 d. Bef 24 Dec 1662
Mary Ball b. 1630 d. 19 Nov 1719
- 6 Mary Pond [1.1.1.1.1.1]
b. 14 May 1657 d. 12 Oct 1732
Simon Gross b. 1652 d. 26 Apr 1696
- 7 Thomas Gross [1.1.1.1.1.1.1]
b. 4 Feb 1678 d. 14 Mar 1727
Experience Freeman b. Abt 1691 d. Bef 18 Nov 1721
- 8 Thomas Gross [1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Oct 1718 d. 1786
Abigail Crowell b. 3 Jun 1715 d. 1756
- 9 Elizabeth Gross [1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 28 Oct 1735 d. Abt 1813
David Newcomb b. 15 Jan 1739 d. 1824
- 10 David Newcomb, Jr. [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 7 Sep 1769 d. 9 Jan 1838
Susanna Mary Kelsey b. 15 May 1774 d. Aft 1837
- 11 Rachel Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1 Apr 1801 d. 1858
- 11 Elizabeth Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 20 Feb 1803 d. 9 Oct 1830
- 11 Calista Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 3 May 1805 d. 18 Jul 1848
- 11 Mary Polly Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 28 Apr 1808 d. 3 May 1883
Orlando Millar b. 25 Mar 1807 d. 17 May 1875
- 12 Ansel Hall Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 17 Aug 1827 d. 11 Feb 1899
- 12 Delania B. Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 9 Sep 1829 d. 1867
- 12 John Leroy Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 29 May 1831 d. 1893
- 12 Lydia Kelsey Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 3 Aug 1833 d. 2 Aug 1905
- 12 Phoebe Ann Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 25 Apr 1835 d. 9 Jul 1846
- 12 Mary Newcomb Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 7 Nov 1836 d. 24 Sep 1864
- 12 Priscilla N. Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 23 Aug 1838 d. 1896
- 12 Rachel Ann Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8]
b. 11 Dec 1840 d. 12 Jan 1907 [ =>]
- 12 Rosette Lent Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.9]
b. 10 Dec 1842 d. 4 Dec 1927
- 12 Orlando D. Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.10]
b. 3 Oct 1844 d. 17 Jun 1861
- 12 David Albert Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.11]
b. 2 Apr 1848 d. 19 Sep 1849
- 12 Jay Willie Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.12]
b. 7 Jun 1851 d. 1 Apr 1865
- 12 Mary Lillie Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.13]
b. 8 Sep 1855 d. 19 Oct 1936
- 12 Ansel Hall Millar [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
- 11 David Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 30 Jan 1810
- 11 Martin Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1 Sep 1811 d. 22 Apr 1863
- 11 Priscilla Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 12 Jul 1814 d. 17 Sep 1883
- 11 Rachel Newcomb [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
- 10 David Newcomb, Jr. [1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
- 9 Elizabeth Gross [1.1.1.1.1.1.1.1.1]
- 8 Thomas Gross [1.1.1.1.1.1.1.1]
- 7 Alice Gross [1.1.1.1.1.1.2]
b. 26 Apr 1689
John Crowell b. 5 Dec 1689 d. Bef 1746
- 8 Abigail Crowell [1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 3 Jun 1715 d. 1756
Thomas Gross b. 9 Oct 1718 d. 1786
- 9 Elizabeth Gross [1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 28 Oct 1735 d. Abt 1813
David Newcomb b. 15 Jan 1739 d. 1824
- 10 David Newcomb, Jr. [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 7 Sep 1769 d. 9 Jan 1838
Susanna Mary Kelsey b. 15 May 1774 d. Aft 1837
- 11 Rachel Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 1 Apr 1801 d. 1858
- 11 Elizabeth Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 20 Feb 1803 d. 9 Oct 1830
- 11 Calista Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.3]
b. 3 May 1805 d. 18 Jul 1848
- 11 Mary Polly Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4]
b. 28 Apr 1808 d. 3 May 1883
Orlando Millar b. 25 Mar 1807 d. 17 May 1875
- 12 Ansel Hall Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.1]
b. 17 Aug 1827 d. 11 Feb 1899
- 12 Delania B. Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.2]
b. 9 Sep 1829 d. 1867
- 12 John Leroy Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.3]
b. 29 May 1831 d. 1893
- 12 Lydia Kelsey Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.4]
b. 3 Aug 1833 d. 2 Aug 1905
- 12 Phoebe Ann Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.5]
b. 25 Apr 1835 d. 9 Jul 1846
- 12 Mary Newcomb Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.6]
b. 7 Nov 1836 d. 24 Sep 1864
- 12 Priscilla N. Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.7]
b. 23 Aug 1838 d. 1896
- 12 Rachel Ann Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.8]
b. 11 Dec 1840 d. 12 Jan 1907 [ =>]
- 12 Rosette Lent Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.9]
b. 10 Dec 1842 d. 4 Dec 1927
- 12 Orlando D. Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.10]
b. 3 Oct 1844 d. 17 Jun 1861
- 12 David Albert Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.11]
b. 2 Apr 1848 d. 19 Sep 1849
- 12 Jay Willie Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.12]
b. 7 Jun 1851 d. 1 Apr 1865
- 12 Mary Lillie Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.13]
b. 8 Sep 1855 d. 19 Oct 1936
- 12 Ansel Hall Millar [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.4.1]
- 11 David Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.5]
b. 30 Jan 1810
- 11 Martin Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.6]
b. 1 Sep 1811 d. 22 Apr 1863
- 11 Priscilla Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.7]
b. 12 Jul 1814 d. 17 Sep 1883
- 11 Rachel Newcomb [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1]
- 10 David Newcomb, Jr. [1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
- 9 Elizabeth Gross [1.1.1.1.1.1.2.1.1]
- 8 Abigail Crowell [1.1.1.1.1.1.2.1]
- 7 Thomas Gross [1.1.1.1.1.1.1]
- 6 Mary Pond [1.1.1.1.1.1]
- 5 Robert Pond, Jr [1.1.1.1.1]
- 4 Robert Pond [1.1.1.1]
- 3 William Pond [1.1.1]
- 2 John Ponder [1.1]