
Samuel Thomas Phillips, Reverand

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Samuel Thomas Phillips, Reverand [1] b. 22 Dec 1624 d. 22 Apr 1696
Sarah Appleton b. 1629 d. 15 Jul 1714
- 2 Sarah Phillips [1.1]
b. 7 Mar 1656 d. 10 Feb 1706
Stephen Mighill b. 27 Dec 1651 d. 16 Apr 1687
- 3 Anne Mighill [1.1.1]
b. 8 Mar 1685 d. 31 May 1764
Benoni Swan Boynton b. 25 Feb 1681 d. 30 Dec 1758
- 4 Sarah Boynton [1.1.1.1]
b. 1700 d. 1794
Samuel Davis b. 1695 d. 1758
- 5 Samuel Davis, III [1.1.1.1.1]
b. 4 Jun 1718 d. 1795
Abigail George b. 5 May 1726 d. 11 Jul 1752
- 6 Elizabeth Davis [1.1.1.1.1.1]
b. 26 Aug 1738 d. 19 Jul 1807
Isaac N. Wiseman, Jr b. 18 Aug 1738 d. 3 May 1818
- 7 Jacob H. Wiseman [1.1.1.1.1.1.1]
b. 12 Jan 1767 d. 15 Jan 1839
Catharine Smalley b. 9 May 1774 d. 1835
- 8 Elizabeth Wiseman [1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1797 d. 1881
Charles William Stewart b. 14 Apr 1791 d. 27 Jul 1877
- 9 Anne Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1827 d. Yes, date unknown
- 9 Robert Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1828 d. 1894
Mary Elizabeth Stewart b. 19 Jul 1837 d. 1896
- 10 Alexander William Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 23 Jul 1862 d. 21 Mar 1951
Bernice Elwood Arthur b. 12 Jul 1882 d. 29 Apr 1972
- 11 Olive Mae Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 6 Jul 1899 d. 8 Dec 1988
George Victory Ott b. 26 Jun 1900 d. 16 Jan 1956
- 12 Betty Jean Ott [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 9 Jan 1926 d. 1 Feb 2009 [ =>]
- 12 Doris Louise Ott [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 1 Sep 1928 d. 17 Apr 2018 [ =>]
- 12 Larry Dean Ott [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 19 Mar 1932 d. 30 Aug 1996 [ =>]
- 12 Betty Jean Ott [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
- 11 Marion E. Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. Mar 1901 d. 1991
- 11 Jean E. Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. Oct 1904 d. 1983
- + Clayton Foster Elderkin b. 29 Oct 1895 d. 1983
- + Clayton Foster Elderkin b. 29 Oct 1895 d. 1983
- 11 Helen Isabel Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 14 Jun 1911 d. 1987
- 11 Alexander Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 20 May 1919 d. 27 Nov 1995
- 11 Olive Mae Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
- 10 Alexander William Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
- 9 James Edward Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 27 Jan 1831 d. 6 Aug 1905
- 9 Daniel Benjamin Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 6 Dec 1835 d. 7 Apr 1870
- 9 John Alex Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 1836 d. 1864
- 9 Malcolm Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 15 Sep 1837
- 9 Joseph B. Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. Sep 1841 d. 1921
- 9 Edward Walter Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 28 Sep 1842 d. 28 Oct 1909
- 9 Anne Stewart [1.1.1.1.1.1.1.1.1]
- 8 Elizabeth Wiseman [1.1.1.1.1.1.1.1]
- 7 Jacob H. Wiseman [1.1.1.1.1.1.1]
- 6 Elizabeth Davis [1.1.1.1.1.1]
- 5 Samuel Davis, III [1.1.1.1.1]
- 4 Sarah Boynton [1.1.1.1]
- 3 Anne Mighill [1.1.1]
- 2 George Phillips [1.2]
b. 3 Jun 1664 d. 3 Apr 1739
Sarah Elizabeth Hallett b. 19 Mar 1673 d. 12 Apr 1730
- 3 George Phillips, Reverend , Jr. [1.2.1]
b. 1 Apr 1698 d. 16 Nov 1771
Elizabeth E. Mills b. 16 Aug 1705 d. 19 Apr 1775
- 4 George Phillips [1.2.1.1]
b. 22 Aug 1719 d. Feb 1778
Hannah Pearl Goad b. 1728 d. Mar 1769
- 5 William Tobias Phillips, Sr [1.2.1.1.1]
b. 25 Jan 1750 d. 2 Jul 1808
Mary Margaret Peggy Jennings b. 1753 d. 1830
- 6 Thomas Burton Phillips [1.2.1.1.1.1]
b. 1781 d. Bef 1860
Abigail Atkins b. 1783 d. 1835
- 7 Sophia Josephine Phillips [1.2.1.1.1.1.1]
b. 1803 d. 1865
Robert Meade Saunders b. Abt 1790 d. Between 1846 and 1850
- 8 S. Saunders [1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 1828 d. Aft 1850
- 8 Isabella Meade Saunders [1.2.1.1.1.1.1.2]
b. 1 Feb 1829 d. 24 Jul 1904
Jesse Albert Byrd b. 4 Feb 1819 d. 25 Dec 1899
- 9 Oliver Perry Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1848 d. 20 Feb 1904
Sarah Jane Perkins b. 1856 d. 19 Aug 1893
- 10 Robert L. Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 1872 d. 24 Feb 1950
- 10 William Edwin Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 1876 d. 17 Feb 1881
- 10 Edith B. Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 1878 d. Yes, date unknown
- 10 Ernest Bertram Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 1886 d. 31 May 1888
- 10 Robert L. Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.1.1]
- 9 Martha W. Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.2]
b. 12 Jul 1850 d. 11 Oct 1852
- 9 William Henry Byrd, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.3]
b. 4 Feb 1852 d. 9 Apr 1911
Clara Matilda Young b. 8 Mar 1869 d. 28 Feb 1934
- 10 Anna Belle Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 18 Sep 1889 d. 13 Aug 1947
Edgar Eugene Baker, Sr. b. 21 Jul 1868 d. 27 Jul 1947
- 11 Phillip Baker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.1]
b. 25 Jan 1912 d. 25 Jan 1912
- 11 Edgar Eugene Baker, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.2]
b. 12 Oct 1913 d. 1 Mar 1992
- + Marian Reed Logan b. 22 Mar 1915 d. 12 Feb 1982
- + Marian Reed Logan b. 22 Mar 1915 d. 12 Feb 1982
- 11 Ruth Baker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.3]
b. 7 Jul 1915 d. 18 Mar 2008
- 11 Helen Baker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.4]
b. 1 Mar 1918 d. May 2000
- + Leo Hughes Moir, Jr b. 25 Jan 1916 d. 5 May 1987
- + Leo Hughes Moir, Jr b. 25 Jan 1916 d. 5 May 1987
- 11 Anna Baker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.5]
b. 31 Dec 1920 d. 12 May 2003
Jack Howard Call, Sr b. 25 Oct 1920 d. 9 Aug 1995
- 12 Michael Eugene Call [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.5.1]
b. 1 Mar 1946 d. 26 Jul 1991
- 12 Michael Eugene Call [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.5.1]
- 11 Charles Byrd Baker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.6]
b. 23 Mar 1930 d. 1 Jul 1967
- 11 Phillip Baker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1.1]
- 10 Henry Leslie Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 8 May 1891 d. 1 May 1966
- + Ethel Ann Kinkler b. 31 Dec 1891 d. 20 Sep 1984
- + Ethel Ann Kinkler b. 31 Dec 1891 d. 20 Sep 1984
- 10 Julia Mae Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 3 May 1895 d. 18 Oct 1967
Harrison Raymond Carlton b. 23 Jan 1889 d. 25 Jun 1975
- 11 Jean Carlton [1.2.1.1.1.1.1.2.3.3.1]
b. 19 Dec 1919 d. 11 Dec 1981
- 11 Harry Raymond Carlton [1.2.1.1.1.1.1.2.3.3.2]
b. 17 Mar 1921 d. 8 Sep 2001
- + Living
- + Living
- 11 Lois Carlton [1.2.1.1.1.1.1.2.3.3.3]
b. 17 Nov 1923 d. 6 Jul 2010
- 11 Sue Carlton [1.2.1.1.1.1.1.2.3.3.4]
b. 17 Jan 1931 d. 29 Jul 2007
- 11 Jean Carlton [1.2.1.1.1.1.1.2.3.3.1]
- 10 Elsie Loraine Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 3 Jun 1898 d. 17 Jun 1980
Guy Vincent Buckman b. 11 Jun 1895 d. 28 Feb 1937
- 11 Clara Ann Buckman [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.1]
b. 26 Apr 1922 d. 23 Nov 2008
Alen Vanderveer Bunker b. 20 Apr 1920 d. 6 Jul 2000
- 12 Barbara Jeanne Bunker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1]
b. 26 Aug 1949 d. 17 Dec 2000
- 12 Living [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2]
- 12 Living [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.1.3]
- 12 Barbara Jeanne Bunker [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1]
- 11 William Enoch Buckman [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.2]
b. 30 Jan 1925 d. 29 Nov 1988
- + Eleanor Ruth Duree b. 3 Oct 1931 d. 14 Nov 2017
- + Sally K. Harvey b. 26 Jul 1927 d. 18 Jul 1991
- + Eleanor Ruth Duree b. 3 Oct 1931 d. 14 Nov 2017
- 11 Guy V Buckman [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.3]
b. 20 Aug 1926 d. 25 Feb 1991
- 11 Clara Ann Buckman [1.2.1.1.1.1.1.2.3.4.1]
- + Booth R. Card b. 23 Feb 1902 d. 25 Mar 1990
- 10 Percy Nelson Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. 8 Mar 1900 d. 20 Mar 1974
- + Wrena Frances Schutt, Rena b. 29 Apr 1910 d. 10 Nov 1993
- + Wrena Frances Schutt, Rena b. 29 Apr 1910 d. 10 Nov 1993
- 10 Jelava Thalia Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.3.6]
b. Apr 1902 d. 18 Sep 1902
- 10 Anna Belle Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.3.1]
- 9 James Robert Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.4]
b. 17 Dec 1853 d. Aft 1900
- 9 Louis Napoleon Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.5]
b. 4 Feb 1857 d. Aft 1900
- 9 Mary Jane Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.6]
b. 21 Jan 1859 d. 14 Jan 1944
Christophe C. Evans b. 19 Feb 1847 d. 9 Feb 1917
- 10 Eugene Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 15 Jun 1875 d. 15 Jun 1875
- 10 Evalina Isabella Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.2]
b. 13 May 1876 d. 10 Jan 1970
- 10 Elmar Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.3]
b. Jun 1878 d. 1879
- 10 Ynez Mason [1.2.1.1.1.1.1.2.6.4]
b. 4 Aug 1880 d. 3 Mar 1966
- 10 Winifred Evans Northey [1.2.1.1.1.1.1.2.6.5]
b. 20 Nov 1882 d. 25 Apr 1968
- 10 Joseph Francis Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.6]
b. 21 Dec 1884 d. 27 Mar 1974
- 10 Louis Napolean Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.7]
b. 5 Feb 1887 d. 10 Feb 1925
- 10 John Christopher Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.8]
b. May 1889 d. 5 Sep 1951
- 10 Carlton J. Patrick Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.9]
b. 8 May 1890 d. 8 Mar 1954
- 10 Eugene Evans [1.2.1.1.1.1.1.2.6.1]
- 9 Sophia Josephine Byrd, Doctor [1.2.1.1.1.1.1.2.7]
b. 13 Sep 1861 d. 1 Dec 1956
James Long McClelland b. Apr 1852 d. 27 Jan 1932
- 10 Elizabeth Isabelle McClelland [1.2.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 4 Mar 1882 d. 4 Nov 1971
- 10 Josephine Esther McClelland [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 7 Jan 1884 d. 7 Apr 1981
- + Ernest Owen Wakeford b. 15 May 1884 d. 26 Sep 1964
Nathan Weston Blanchard, Jr. b. 16 Oct 1873 d. 5 Feb 1932
- 11 Nathan Weston Blanchard, III [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.1]
b. 19 Nov 1908 d. 8 Jun 1999
- 11 Hobbs Blanchard [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.2]
b. 1 Jan 1912 d. 6 Mar 1999
- 11 Eliot Mcclelland Blanchard [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.3]
b. 7 Jul 1914 d. 20 Jul 1965
Elizabeth Irene Munger b. 18 Mar 1917 d. 29 Sep 2009
- 12 Living [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.3.1]
- 12 James Eliot Blanchard [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.3.2]
b. 1 Jul 1941 d. 14 Nov 2014
- 12 Living [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.3.3]
- 12 Living [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.3.1]
- 11 Thomas Goodwin Blanchard [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.4]
b. 27 Sep 1917 d. 21 May 1918
- 11 Nathan Weston Blanchard, III [1.2.1.1.1.1.1.2.7.2.1]
- + Ernest Owen Wakeford b. 15 May 1884 d. 26 Sep 1964
- 10 James Hugh McClelland, Doctor [1.2.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 15 Apr 1888 d. 18 Dec 1948
Mary Agnes McGraw b. 26 Dec 1888 d. 22 Apr 1964
- 11 Margaret Jane McClelland [1.2.1.1.1.1.1.2.7.3.1]
b. 21 Jun 1916 d. 9 Oct 1985
John Augustus Sperry, Jr. b. 29 Jan 1913 d. 6 May 1979
- 12 John Mcclelland Sperry [1.2.1.1.1.1.1.2.7.3.1.1]
b. 13 Jan 1938 d. 14 Jan 1938
- 12 Suzanne Marie Sperry [1.2.1.1.1.1.1.2.7.3.1.2]
b. 21 Jul 1941 d. 21 Mar 2006
- 12 James Hugh Sperry [1.2.1.1.1.1.1.2.7.3.1.3]
b. 9 Dec 1942 d. 31 Jan 2019
- 12 John Mcclelland Sperry [1.2.1.1.1.1.1.2.7.3.1.1]
- + Jethro Fontaine b. 9 Jan 1916 d. 17 Mar 1987
- 11 Margaret Jane McClelland [1.2.1.1.1.1.1.2.7.3.1]
- 10 Elizabeth Isabelle McClelland [1.2.1.1.1.1.1.2.7.1]
- + John Olson b. Abt 1868 d. Yes, date unknown
- 9 George Albert Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.8]
b. 21 Sep 1865 d. 2 Dec 1950
Lucinda Belle Hector b. 12 Dec 1867 d. 29 Mar 1911
- 10 Hugh G. Byrd, Sr [1.2.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 23 Nov 1899 d. 22 Jan 1973
- 10 Hugh G. Byrd, Sr [1.2.1.1.1.1.1.2.8.1]
- + Christianna Weaver b. 29 Nov 1859 d. 30 Oct 1945
- 9 Percy Ira Leonidas Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.9]
b. 13 Jul 1867 d. 15 Aug 1877
- 9 Francis M. Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.10]
b. 13 Apr 1869 d. Aft 1910
- + Myrtle Lemmon b. 1882 d. Yes, date unknown
- + Myrtle Lemmon b. 1882 d. Yes, date unknown
- 9 Oliver Perry Byrd [1.2.1.1.1.1.1.2.1]
- 8 Winfield Scott Saunders [1.2.1.1.1.1.1.3]
b. 4 Sep 1834 d. 1 Mar 1910
Margaret E. Spear b. Abt 1848 d. Abt 1878
- 9 Ellen Josephine Saunders [1.2.1.1.1.1.1.3.1]
b. Jun 1864 d. 24 Apr 1911
Louis Asberry Rose b. 13 Jan 1858 d. 3 Oct 1941
- 10 Lillie Margaret Rose [1.2.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 1 Feb 1883 d. 6 Oct 1956
- 10 Lulu Josephine Rose [1.2.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 5 Sep 1886 d. 3 Nov 1949
- 10 Florence R. Rose [1.2.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. Sep 1888 d. Bef 1910
- 10 Bertha Blanche Rose [1.2.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 31 Aug 1890 d. 19 Jul 1984
- 10 Louis Asberry Rose, Jr. [1.2.1.1.1.1.1.3.1.5]
b. 5 Jan 1892 d. 9 Sep 1944
- 10 Lillie Margaret Rose [1.2.1.1.1.1.1.3.1.1]
- 9 John Alexander Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.2]
b. 12 Nov 1866 d. 29 Apr 1946
- 9 Lola Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.3]
b. Abt 1867 d. Yes, date unknown
- 9 Albert W. Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.4]
b. 11 Nov 1868 d. 6 May 1918
Nellie Ann Johnson b. 27 May 1872 d. 7 Dec 1956
- 10 Jacob Emery Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 1895 d. May 1916
- 10 Jacob Emery Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.4.1]
- 9 Ellen Josephine Saunders [1.2.1.1.1.1.1.3.1]
Caroline McCreary b. 4 Apr 1839 d. 28 Mar 1922
- 9 Minnie Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.5]
b. Feb 1881 d. Bef 1953
- 9 Harriet E. Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.6]
b. 23 Apr 1883 d. 24 Dec 1959
- 9 Minnie Sanders [1.2.1.1.1.1.1.3.5]
- 8 Susan Jane Sanders [1.2.1.1.1.1.1.4]
b. 10 Mar 1840 d. 29 Jun 1906
- 8 S. Saunders [1.2.1.1.1.1.1.1]
- 7 Sophia Josephine Phillips [1.2.1.1.1.1.1]
- 6 Thomas Burton Phillips [1.2.1.1.1.1]
- 5 William Tobias Phillips, Sr [1.2.1.1.1]
- 4 George Phillips [1.2.1.1]
- 3 George Phillips, Reverend , Jr. [1.2.1]
- 2 Sarah Phillips [1.1]